Statuts Refondus de la Province de Québec, 1941, المجلد 4Imprimé par R. Paradis, imprimeur du roi, 1941 |
من داخل الكتاب
النتائج 1-3 من 81
الصفحة 12
... shall suspend the execution of the vient exécutoire aussitôt que l'appel est decision . The latter shall become execu- rejeté ou abandonné et en l'absence tory as soon as the appeal has been dis- d'appel , à l'expiration du délai pour ...
... shall suspend the execution of the vient exécutoire aussitôt que l'appel est decision . The latter shall become execu- rejeté ou abandonné et en l'absence tory as soon as the appeal has been dis- d'appel , à l'expiration du délai pour ...
الصفحة 156
... shall be professors of the cine des universités mentionnées à l'article faculties of medicine of the universities 5 ... shall remain in office for four years . R. S. 1925 , c . 213 , s . 37 . 38. The date of the examinations and Examina ...
... shall be professors of the cine des universités mentionnées à l'article faculties of medicine of the universities 5 ... shall remain in office for four years . R. S. 1925 , c . 213 , s . 37 . 38. The date of the examinations and Examina ...
الصفحة 668
... shall aid or abet règlement émanant de la Régie des ser- therein , or shall wilfully omit or fail to do vices publics relativement aux taux des any act , matter or thing thereby required transports , ou qui y participe ou coopère , to ...
... shall aid or abet règlement émanant de la Régie des ser- therein , or shall wilfully omit or fail to do vices publics relativement aux taux des any act , matter or thing thereby required transports , ou qui y participe ou coopère , to ...
عبارات ومصطلحات مألوفة
actionnaires actions admission advocate amende amount annuelle appeal apply Arthabaska assemblée association Attorney-General avis batonnier bureau business by-laws Canada candidate certificat charte College compagnie company conseil général copie copy corporation costs créan creditors date deed dental directors dismissal dispositions district DIVISION documents dollars election entitled examination fees General Council general meeting given head office held holder hundred immoveable l'article land surveyor lettres patentes liable lieutenant-gouverneur liquidators made make management manner member membres ment mentioned Montréal name notaire notary notice offence office officers one hundred dollars optométriste order paid paiement pany payment penalty person powers practice practising présente loi président profession property provided province de Québec Province of Quebec Provincial provisions purpose quorum registered registrar registration règlements required right same secrétaire secrétaire-trésorier secretary secretary-treasurer section security shareholder shareholders shares société special stock study Superior Court syndic thereof time tion treasurer under oath unless vote year